-
4WAY HOLDING LTD - 5 Manchester Square, London, W1U 3PD, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07232882
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 Manchester Square
- London
- W1U 3PD
- England 5 Manchester Square, London, W1U 3PD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GODDARD, Jonathan Bruce
- LEE, Adam
- WESTWOOD, John David
- Prokuristen
- ROBERTS, Linda Susan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.04.2010
- Gelöscht am:
- 2021-04-13
- SIC/NACE
- 71122
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- Pell Frischmann Consulting Engineers Ltd.
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- 4 WAY CONSULTING LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-07
- Letzte Einreichung: 2020-04-23
-
4WAY HOLDING LTD Firmenbeschreibung
- 4WAY HOLDING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07232882. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.04.2010 registriert. 4WAY HOLDING LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen 4 WAY CONSULTING LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71122" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.04.2012.Die Firma kann schriftlich über 5 Manchester Square erreicht werden.
Jetzt sichern 4WAY HOLDING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 4Way Holding Ltd - 5 Manchester Square, London, W1U 3PD, England, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 4WAY HOLDING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-04-13) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-01-19) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-01-26) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-07-02) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-05-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-11-02) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-29) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-03) - CH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-05-25) - AP03
keyboard_arrow_right 2017
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-08) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-14) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-22) - AP01
-
resolution (2017-09-27) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-08) - PSC02
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-10-03) - SH02
-
capital-allotment-shares (2017-10-03) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-18) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-09-08) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-08) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-08) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-13) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-of-name-notice (2014-05-01) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2014-05-01) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-06) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-06) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-07-15) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-04-23) - NEWINC