-
DUNE FINANCIAL PLANNING LIMITED - 21-27 St Pauls Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 2JG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08121664
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 21-27 St Pauls Street
- Leeds
- West Yorkshire
- LS1 2JG 21-27 St Pauls Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 2JG UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.06.2012
- Alter der Firma 2012-06-27 12 Jahre
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Dune Financial Holdings Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SIMPSON MILLAR FINANCIAL SERVICES LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800UL8JXYTS9IDS85
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-26
- Letzte Einreichung: 2020-03-12
-
DUNE FINANCIAL PLANNING LIMITED Firmenbeschreibung
- DUNE FINANCIAL PLANNING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08121664. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.06.2012 registriert. DUNE FINANCIAL PLANNING LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SIMPSON MILLAR FINANCIAL SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2013 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 21-27 St Pauls Street erreicht werden.
Jetzt sichern DUNE FINANCIAL PLANNING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dune Financial Planning Limited - 21-27 St Pauls Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 2JG, Grossbritannien
- 2012-06-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DUNE FINANCIAL PLANNING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-08-10) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-08-08) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-04) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-02-01) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-04) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-04) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-04) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-17) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-10) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-08-10) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-10) - TM01
-
change-of-name-notice (2017-09-15) - CONNOT
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-09-08) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-26) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-26) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-04) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-29) - MR01
-
resolution (2017-09-15) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-10) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-13) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-03) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-10-03) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-03) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-04) - AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-06-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-13) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-21) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-10) - AP03
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-11-07) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-28) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-16) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-25) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-15) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-06-27) - NEWINC