-
TRX VASCULAR LIMITED - Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way, Garforth, Leeds, LS25 2GY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08161610
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way
- Garforth
- Leeds
- LS25 2GY
- England Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way, Garforth, Leeds, LS25 2GY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COCKE, David Claiborne
- GLENN, Jonathan Martin
- LEE, Daniel Ray
- Prokuristen
- LUND, Kirsten Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-30 12 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Tissue Regenix Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-13
- Letzte Einreichung: 2023-07-30
-
TRX VASCULAR LIMITED Firmenbeschreibung
- TRX VASCULAR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08161610. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way erreicht werden.
Jetzt sichern TRX VASCULAR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trx Vascular Limited - Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way, Garforth, Leeds, LS25 2GY, Grossbritannien
- 2012-07-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRX VASCULAR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
dissolution-application-strike-off-company (2024-01-02) - DS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-03-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-09-20) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-02) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-10) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-11-04) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-28) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-30) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-12-23) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-23) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-10-11) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-08-23) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-11-12) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-06) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-02-20) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-07) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-13) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-01-12) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-13) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-01) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-11-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-24) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-07-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-09-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-09-13) - AA01
-
incorporation-company (2012-07-30) - NEWINC