-
SMAILES GOLDIE LIMITED - Regent's Court, Princess Street, Hull, East Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08434147
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Regent's Court
- Princess Street
- Hull
- East Yorkshire
- HU2 8BA Regent's Court, Princess Street, Hull, East Yorkshire, HU2 8BA UK
Management
- Geschäftsführung
- BRAMALL, Stephen Thomas
- DEARING, Peter Alan
- LAMB, Ian Robert
- OVERFIELD, Martin
- SHIPLEY, Nicola
- STOCKS, Mike James
- TAYLOR, Luke Damien
- COWELL, William
- FOX, Matthew Liam
- SHANNON, Victoria
- THIIM, Benjamin John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-07 11 Jahre
- SIC/NACE
- 69201
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SMAILES GOLDIE TURNER LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-03-25
- Letzte Einreichung: 2022-03-11
-
SMAILES GOLDIE LIMITED Firmenbeschreibung
- SMAILES GOLDIE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08434147. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.03.2013 registriert. SMAILES GOLDIE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SMAILES GOLDIE TURNER LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69201" registriert. Das Unternehmen hat 11 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Regent's Court erreicht werden.
Jetzt sichern SMAILES GOLDIE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Smailes Goldie Limited - Regent's Court, Princess Street, Hull, East Yorkshire, Grossbritannien
- 2013-03-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMAILES GOLDIE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-02-01) - AP01
-
capital-allotment-shares (2023-02-01) - SH01
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-08-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-21) - AA
-
memorandum-articles (2022-08-24) - MA
-
resolution (2022-08-24) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2022-08-22) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-08-22) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2022-08-15) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2022-08-15) - SH03
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-cancellation-shares (2020-04-02) - SH06
-
resolution (2020-03-12) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-23) - AA
-
resolution (2020-04-02) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-09) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-11) - CS01
-
memorandum-articles (2020-05-18) - MA
-
memorandum-articles (2020-04-21) - MA
-
change-of-name-notice (2020-06-29) - CONNOT
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-05-21) - SH03
-
resolution (2020-06-29) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-12) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-07-29) - SH01
-
resolution (2019-07-30) - RESOLUTIONS
-
resolution (2019-09-16) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2019-09-16) - MA
-
capital-cancellation-shares (2019-10-16) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-10-30) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-06) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-11) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-07) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-03-07) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-29) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2013-05-07) - CERTNM
-
resolution (2013-05-15) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-05-15) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-05-15) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-01) - MR01