-
EMSLEYS SOLICITORS LIMITED - Colton Mill, Bullerthorpe Lane, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08708277
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Colton Mill
- Bullerthorpe Lane
- Leeds
- West Yorkshire
- LS15 9JN Colton Mill, Bullerthorpe Lane, Leeds, West Yorkshire, LS15 9JN UK
Management
- Geschäftsführung
- GREENWOOD, Andrew Leslie
- HUTCHINGS, John Paul
- HOGG, Judith
- PUJARA, Corinne Lesley
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.09.2013
- Alter der Firma 2013-09-27 11 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Alistair Mckinlay
- Mr Andrew Leslie Greenwood
- Mr Alistair Mckinlay
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-11
- Letzte Einreichung: 2020-09-27
-
EMSLEYS SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- EMSLEYS SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08708277. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.09.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Colton Mill erreicht werden.
Jetzt sichern EMSLEYS SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Emsleys Solicitors Limited - Colton Mill, Bullerthorpe Lane, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2013-09-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EMSLEYS SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-19) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-23) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-12) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-04) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-03) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-03) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-04) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-19) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-28) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-11-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-02) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-21) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-01-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-01) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2018-10-23) - SH06
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-07) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-22) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-24) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-02-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-30) - CH01
-
capital-cancellation-shares (2016-02-12) - SH06
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-08) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-02-12) - SH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-30) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-05-18) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-05-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-10) - CH01
-
memorandum-articles (2014-05-12) - MEM/ARTS
-
resolution (2014-05-12) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-05-12) - SH10
-
capital-alter-shares-consolidation (2014-05-12) - SH02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-08) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-06) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-09-27) - NEWINC