-
CROSSWAYS ANIMAL CARE LIMITED - The Chocolate Factory Somerdale, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08914273
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Chocolate Factory Somerdale
- Keynsham
- Bristol
- BS31 2AU
- England The Chocolate Factory Somerdale, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GILLINGS, Mark Andrew
- SIMPSON, Donna Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Independent Vetcare Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-14
- Letzte Einreichung: 2023-02-28
-
CROSSWAYS ANIMAL CARE LIMITED Firmenbeschreibung
- CROSSWAYS ANIMAL CARE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08914273. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.02.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Chocolate Factory Somerdale erreicht werden.
Jetzt sichern CROSSWAYS ANIMAL CARE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Crossways Animal Care Limited - The Chocolate Factory Somerdale, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Grossbritannien
- 2014-02-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CROSSWAYS ANIMAL CARE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-13) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-05-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-12-07) - PSC05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-06-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-10-25) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-28) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-09) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-26) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-03-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-06-17) - AA
-
legacy (2020-06-05) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-06-05) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-06-17) - PARENT_ACC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-19) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-19) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-21) - AD01
-
resolution (2019-03-06) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-11) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-21) - MR04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-09) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-02) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-14) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-19) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-15) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-16) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-18) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-26) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-09-28) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2017-09-28) - SH06
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-30) - PSC07
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-26) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-11-25) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-02-27) - NEWINC