-
NAUGHTY CORNER PRODUCTIONS LTD - 6 Horstone Gardens, Great Sutton, Ellesmere Port, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09283909
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6 Horstone Gardens
- Great Sutton
- Ellesmere Port
- Cheshire
- CH66 2JL 6 Horstone Gardens, Great Sutton, Ellesmere Port, Cheshire, CH66 2JL UK
Management
- Geschäftsführung
- MR MICHAEL RONALD DICKINSON
- MISS JEMMA LOUISE LYNCH
- MR THOMAS EDWARD LYTH
- DICKINSON, Michael Ronald
- DUFFY, Trisha
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-28 9 Jahre
- SIC/NACE
- 90010
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Ronald Dickinson
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-29
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-06-07
- Letzte Einreichung: 2024-05-24
-
NAUGHTY CORNER PRODUCTIONS LTD Firmenbeschreibung
- NAUGHTY CORNER PRODUCTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09283909. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.10.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "90010" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 6 Horstone Gardens erreicht werden.
Jetzt sichern NAUGHTY CORNER PRODUCTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Naughty Corner Productions Ltd - 6 Horstone Gardens, Great Sutton, Ellesmere Port, Cheshire, Grossbritannien
- 2014-10-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NAUGHTY CORNER PRODUCTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-24) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2024-01-26) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-27) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-04-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-24) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-24) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-24) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-24) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-24) - PSC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-08) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-07-18) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-10) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2015-11-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-17) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-14) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-13) - AP01
-
incorporation-company (2014-10-28) - NEWINC