-
TOP PRINT LIMITED - Chandler House, 7 Ferry Road Office Park, Riversway, Preston, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04494089
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Chandler House
- 7 Ferry Road Office Park
- Riversway
- Preston
- PR2 2YH Chandler House, 7 Ferry Road Office Park, Riversway, Preston, PR2 2YH UK
Management
- Geschäftsführung
- BARLOW, Julie
- Prokuristen
- WNJ SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.07.2002
- Alter der Firma 2002-07-24 22 Jahre
- SIC/NACE
- 18129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael David Barlow
- Mrs Julie Barlow
- Mrs Julie Barlow
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-07
- Letzte Einreichung: 2020-07-24
-
TOP PRINT LIMITED Firmenbeschreibung
- TOP PRINT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04494089. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.07.2002 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "18129" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Chandler House erreicht werden.
Jetzt sichern TOP PRINT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Top Print Limited - Chandler House, 7 Ferry Road Office Park, Riversway, Preston, Grossbritannien
- 2002-07-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOP PRINT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-02) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-31) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-07-02) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-18) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-08) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2014-09-08) - CH04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2013-10-23) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name (2013-10-23) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-17) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-08-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-24) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-16) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-07) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-10-05) - AA
-
legacy (2007-09-15) - 363s
-
legacy (2007-02-12) - 225
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-10-31) - AA
-
legacy (2006-08-17) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-07-21) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-12-01) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-12-22) - AA
-
legacy (2004-10-05) - 363s
-
legacy (2004-07-21) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-03-12) - AA
-
legacy (2004-03-12) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-08-08) - 287
-
legacy (2003-08-08) - 363s
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-08-01) - 288b
-
legacy (2002-08-01) - 288a
-
incorporation-company (2002-07-24) - NEWINC