-
J H CONTRACT SERVICES LIMITED - 2 Mountsdie, Stanmore, Middlesex, HA7 2DT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04616077
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Mountsdie
- Stanmore
- Middlesex
- HA7 2DT 2 Mountsdie, Stanmore, Middlesex, HA7 2DT UK
Management
- Geschäftsführung
- HAND, Charlotte Ann
- SANDS, Charlotte Ann
- Prokuristen
- HAND, Brendan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.12.2002
- Alter der Firma 2002-12-12 21 Jahre
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter John Hand
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Ehemalige Namen
- JH PLANT SERVICES LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-12-23
- Letzte Einreichung: 2021-12-09
-
J H CONTRACT SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- J H CONTRACT SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04616077. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.12.2002 registriert. J H CONTRACT SERVICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JH PLANT SERVICES LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 2 Mountsdie erreicht werden.
Jetzt sichern J H CONTRACT SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: J H Contract Services Limited - 2 Mountsdie, Stanmore, Middlesex, HA7 2DT, Grossbritannien
- 2002-12-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu J H CONTRACT SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-06-08) - DISS16(SOAS)
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-14) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2022-05-31) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-12-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-13) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-18) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-06) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-05) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-31) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-01-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-02) - AA
-
legacy (2009-02-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
certificate-change-of-name-company (2008-10-15) - CERTNM
-
legacy (2008-10-16) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-04-07) - AA
-
legacy (2008-12-22) - 363a
-
legacy (2008-10-20) - 287
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-02-02) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-08-19) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-07-26) - AA
-
legacy (2005-05-09) - 225
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-03-12) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-01-13) - 287
-
legacy (2003-01-13) - 288a
-
certificate-change-of-name-company (2003-01-10) - CERTNM
-
legacy (2003-01-17) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-12-23) - 288b
-
incorporation-company (2002-12-12) - NEWINC