-
MILVERTON SCHOOL LIMITED - C/O Duff & Phelps Ltd, 35 Newhall Street, Birmingham, B3 3PU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05497573
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Duff & Phelps Ltd
- 35 Newhall Street
- Birmingham
- B3 3PU C/O Duff & Phelps Ltd, 35 Newhall Street, Birmingham, B3 3PU UK
Management
- Geschäftsführung
- CHAMBERLAIN, Simon Neville
- Prokuristen
- CHAMBERLAIN, Simon Neville
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.07.2005
- Gelöscht am:
- 2021-03-03
- SIC/NACE
- 85200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Neville Chamberlain
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-05-31
- Letzte Einreichung: 2018-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-14
- Letzte Einreichung: 2019-07-03
-
MILVERTON SCHOOL LIMITED Firmenbeschreibung
- MILVERTON SCHOOL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05497573. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 03.07.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85200" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Duff & Phelps Ltd erreicht werden.
Jetzt sichern MILVERTON SCHOOL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Milverton School Limited - C/O Duff & Phelps Ltd, 35 Newhall Street, Birmingham, B3 3PU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MILVERTON SCHOOL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-11-26) - LIQ10
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-01) - REC2
-
liquidation-receiver-cease-to-act-receiver (2020-09-01) - RM02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-11-06) - 600
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-12-03) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-09) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-09-07) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-07) - 600
-
resolution (2019-09-07) - RESOLUTIONS
-
liquidation-receiver-appointment-of-receiver (2019-09-04) - RM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-09) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-16) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-16) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-02) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-09-05) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-16) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-10) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-06) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-05) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-24) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-06-23) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-05-05) - AA
-
legacy (2009-09-01) - 287
-
legacy (2009-09-10) - 225
-
legacy (2009-09-24) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-08) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-small (2008-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-10) - 363a
-
legacy (2007-07-10) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-small (2007-05-21) - AA
-
legacy (2007-05-08) - 225
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-08-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
incorporation-company (2005-07-03) - NEWINC
-
legacy (2005-08-17) - 395
-
legacy (2005-09-01) - 395