-
EDENSHIRE PROPERTIES LTD - 48 - 52, Penny Lane Mossley Hill, Liverpool, Merseyside, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05528772
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 48 - 52
- Penny Lane Mossley Hill
- Liverpool
- Merseyside
- L18 1DG 48 - 52, Penny Lane Mossley Hill, Liverpool, Merseyside, L18 1DG UK
Management
- Geschäftsführung
- HUGH, Liam
- LOWRIE, Gary Anthony
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.08.2005
- Alter der Firma 2005-08-05 19 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Liam Hugh
- Mr Gary Anthony Lowrie
- Mr Liam Hugh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-19
- Letzte Einreichung: 2020-08-05
-
EDENSHIRE PROPERTIES LTD Firmenbeschreibung
- EDENSHIRE PROPERTIES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05528772. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.08.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 48 - 52 erreicht werden.
Jetzt sichern EDENSHIRE PROPERTIES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Edenshire Properties Ltd - 48 - 52, Penny Lane Mossley Hill, Liverpool, Merseyside, Grossbritannien
- 2005-08-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EDENSHIRE PROPERTIES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-12-03) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-02) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-01) - PSC04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-19) - MR04
-
gazette-notice-compulsory (2020-12-01) - GAZ1
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-12-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-31) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-11) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-11) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-24) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-09-24) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-09-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-09) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-08-30) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-31) - AA
-
legacy (2013-03-14) - MG01
-
legacy (2013-03-13) - MG01
-
legacy (2013-03-06) - MG01
-
legacy (2013-03-01) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-09) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-09) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-06-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-04-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-28) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-29) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-09-29) - CH04
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-07) - 363a
-
legacy (2009-08-04) - 395
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-07-16) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-11-17) - AA
-
legacy (2008-11-05) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-02-06) - 288a
-
legacy (2007-02-06) - 88(2)R
-
legacy (2007-11-13) - 288c
-
legacy (2007-11-28) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-11-07) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-10-14) - 288a
-
legacy (2005-09-01) - 287
-
legacy (2005-09-01) - 288b
-
incorporation-company (2005-08-05) - NEWINC