-
ENERGIZED WORK LIMITED - 257b, Croydon Road, Beckenham, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06271339
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 257b
- Croydon Road
- Beckenham
- Kent
- BR3 3PS 257b, Croydon Road, Beckenham, Kent, BR3 3PS UK
Management
- Geschäftsführung
- AVIRAM, Yoav
- BAKER, Simon John
- Prokuristen
- BAKER, Simon John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.06.2007
- Gelöscht am:
- 2020-07-24
- SIC/NACE
- 62020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon John Baker
- Yoav Aviram
- Fergus Power
- Yoav Aviram
- Fergus Power
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-06
-
ENERGIZED WORK LIMITED Firmenbeschreibung
- ENERGIZED WORK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06271339. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.06.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62020" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 257B erreicht werden.
Jetzt sichern ENERGIZED WORK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Energized Work Limited - 257b, Croydon Road, Beckenham, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ENERGIZED WORK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-07-24) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-04-24) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-07-30) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-07-30) - 600
-
resolution (2019-07-30) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-07-29) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-13) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-07-03) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2018-07-03) - SH06
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-06) - AAMD
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-02-13) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2017-02-24) - SH06
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2017-02-27) - RP04AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-07) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-20) - CS01
-
legacy (2017-12-11) - RP04CS01
-
resolution (2017-03-01) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-08-02) - SH02
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-24) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-07-14) - SH08
-
resolution (2016-07-13) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-12) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-06-30) - CH03
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-09) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-02-06) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-05) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-22) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-06) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-10) - AA
-
legacy (2009-06-16) - 363a
-
legacy (2009-06-16) - 288c
-
legacy (2009-01-08) - 287
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-09-24) - AA
-
legacy (2008-06-25) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
incorporation-company (2007-06-06) - NEWINC