-
GLOVERS COURT PRESTON LIMITED - 2 Commercial Street, Manchester, M15 4RQ, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06532350
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Commercial Street
- Manchester
- M15 4RQ
- England 2 Commercial Street, Manchester, M15 4RQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CASEY, Robert Bernard
- ROBINSON, David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.03.2008
- Alter der Firma 2008-03-12 16 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Frank Bretherton
- Mr Robert Bernard Casey
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-23
- Letzte Einreichung: 2020-11-09
-
GLOVERS COURT PRESTON LIMITED Firmenbeschreibung
- GLOVERS COURT PRESTON LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06532350. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.03.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2 Commercial Street erreicht werden.
Jetzt sichern GLOVERS COURT PRESTON LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Glovers Court Preston Limited - 2 Commercial Street, Manchester, M15 4RQ, England, Grossbritannien
- 2008-03-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GLOVERS COURT PRESTON LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-11-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-09) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-09) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-09) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-16) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-09) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-09) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-13) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-23) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-12) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-02) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-20) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-12) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-12) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-04-18) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-12-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-11) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-07-08) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-04) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-10-29) - AA
-
legacy (2009-08-10) - 288c
-
legacy (2009-05-18) - 288c
-
legacy (2009-04-17) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-03-31) - 287
-
legacy (2008-03-31) - 288b
-
legacy (2008-03-31) - 288a
-
incorporation-company (2008-03-12) - NEWINC