-
CAVENDISH FILTERS LTD - UNIT 7, St Marys Works, Burnmoor Street, Leicester, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06626435
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- UNIT 7
- St Marys Works
- Burnmoor Street
- Leicester
- LE2 7JL UNIT 7, St Marys Works, Burnmoor Street, Leicester, LE2 7JL UK
Management
- Geschäftsführung
- RUTHERFORD, James Ian
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.06.2008
- Alter der Firma 2008-06-23 16 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr James Ian Rutherford
- Mrs Sasithon Rutherford
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-15
- Letzte Einreichung: 2022-06-01
-
CAVENDISH FILTERS LTD Firmenbeschreibung
- CAVENDISH FILTERS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06626435. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.06.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 7 erreicht werden.
Jetzt sichern CAVENDISH FILTERS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cavendish Filters Ltd - UNIT 7, St Marys Works, Burnmoor Street, Leicester, Grossbritannien
- 2008-06-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAVENDISH FILTERS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-29) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-05-16) - PSC04
-
capital-cancellation-shares (2023-06-09) - SH06
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-03-02) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-08) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-10-26) - PSC04
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-06-12) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-04) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-11-05) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-11-05) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-12) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-25) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-11-18) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2013-06-10) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-06-10) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-10) - AD01
-
capital-allotment-shares (2011-12-12) - SH01
-
capital-allotment-shares (2011-12-09) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-12) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-31) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-03-31) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-03-31) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
termination-secretary-company-with-name (2009-11-17) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-10-09) - AD01
-
legacy (2009-07-16) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-28) - 225
-
incorporation-company (2008-06-23) - NEWINC
-
legacy (2008-08-28) - 287