-
32 LA LIMITED - 32 Lloyds Avenue, Ipswich, Suffolk, IP1 3HD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06703505
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 32 Lloyds Avenue
- Ipswich
- Suffolk
- IP1 3HD 32 Lloyds Avenue, Ipswich, Suffolk, IP1 3HD UK
Management
- Geschäftsführung
- AWAD, Peter Frank
- RILEY, Jane Elizabeth
- SINGH, Kimat
- CLEMENCE, Matthew Edward
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.09.2008
- Alter der Firma 2008-09-22 16 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Peter Frank Awad
- -
- Mr Peter Frank Awad
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-16
- Letzte Einreichung: 2023-06-02
-
32 LA LIMITED Firmenbeschreibung
- 32 LA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06703505. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.09.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 32 Lloyds Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern 32 LA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 32 La Limited - 32 Lloyds Avenue, Ipswich, Suffolk, IP1 3HD, Grossbritannien
- 2008-09-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 32 LA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-06-08) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-06-14) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-06-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-31) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-07-03) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-03-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-10) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-12-10) - PSC09
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-07-11) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-09) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-07-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-15) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-11-08) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-29) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-05-08) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-15) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-29) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-13) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-07) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-23) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-03-31) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2010-03-30) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-03-30) - TM02
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-22) - 363a
-
legacy (2009-09-22) - 288c
-
legacy (2009-09-03) - 395
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-17) - 288a
-
incorporation-company (2008-09-22) - NEWINC