-
GREEN EUROPE SOLUTIONS LIMITED - The Green Group Warwick Road, Maltby, Rotherham, South Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06717157
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Green Group Warwick Road
- Maltby
- Rotherham
- South Yorkshire
- S66 8EW The Green Group Warwick Road, Maltby, Rotherham, South Yorkshire, S66 8EW UK
Management
- Geschäftsführung
- HOYES, Nicolas Arnold
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.10.2008
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Lawson Carswell Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- closed 6+ years
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-10-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-21
- Letzte Einreichung: 2020-10-07
-
GREEN EUROPE SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- GREEN EUROPE SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06717157. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.10.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.10.2014.Die Firma kann schriftlich über The Green Group Warwick Road erreicht werden.
Jetzt sichern GREEN EUROPE SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Green Europe Solutions Limited - The Green Group Warwick Road, Maltby, Rotherham, South Yorkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREEN EUROPE SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-08-05) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-07) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-10-07) - PSC02
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-05-18) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-02) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-15) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-08) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-01) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-31) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-01-01) - DISS40
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-31) - AR01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2012-12-22) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2012-10-30) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-29) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-29) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-31) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2012-05-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-31) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-05-31) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-02) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-17) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-06-17) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-07-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-11-29) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-09-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-24) - AR01
-
legacy (2009-02-17) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-09) - 287
-
legacy (2008-10-09) - 288b
-
incorporation-company (2008-10-07) - NEWINC