-
WESTFIELD PROPERTY SOLUTIONS LTD. - 13 Westfield Terrace, Sheffield, South Yorkshire, S1 4GH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06821011
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 13 Westfield Terrace
- Sheffield
- South Yorkshire
- S1 4GH 13 Westfield Terrace, Sheffield, South Yorkshire, S1 4GH UK
Management
- Geschäftsführung
- CLIFTON, Peter Stanley
- ROBERTSON, Paul
- Prokuristen
- ROBERTSON, Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.02.2009
- Alter der Firma 2009-02-17 15 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ALBANY ROBERTSON LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-08
- Letzte Einreichung: 2020-06-24
-
WESTFIELD PROPERTY SOLUTIONS LTD. Firmenbeschreibung
- WESTFIELD PROPERTY SOLUTIONS LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06821011. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.02.2009 registriert. WESTFIELD PROPERTY SOLUTIONS LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ALBANY ROBERTSON LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 29/02/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.02.2013.Die Firma kann schriftlich über 13 Westfield Terrace erreicht werden.
Jetzt sichern WESTFIELD PROPERTY SOLUTIONS LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Westfield Property Solutions Ltd. - 13 Westfield Terrace, Sheffield, South Yorkshire, S1 4GH, Grossbritannien
- 2009-02-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WESTFIELD PROPERTY SOLUTIONS LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-28) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-01-28) - CH03
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-10-06) - PSC08
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-06) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-micro-entity (2018-07-06) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-10) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-07) - CS01
-
mortgage-charge-part-release-with-charge-number (2017-09-27) - MR05
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-09-02) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-24) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-24) - AAMD
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-26) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-02-26) - CH03
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-02-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-21) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-10-22) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-24) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2012-02-29) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-30) - AR01
-
change-of-name-notice (2012-02-29) - CONNOT
-
legacy (2012-09-14) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-13) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-27) - AR01
-
capital-allotment-shares (2010-07-23) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
certificate-change-of-name-company (2009-02-25) - CERTNM
-
incorporation-company (2009-02-17) - NEWINC