-
YORKSHIRE PHYSIOTHERAPY NETWORK LIMITED - 42 Lidget Hill, Pudsey, LS28 7DR, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06846871
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 42 Lidget Hill
- Pudsey
- LS28 7DR
- England 42 Lidget Hill, Pudsey, LS28 7DR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BETTS, Paul Aaron
- TAYLOR, Matthew Richard
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.03.2009
- Gelöscht am:
- 2021-08-10
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Sano Physiotherapy Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-18
- Letzte Einreichung: 2021-02-04
-
YORKSHIRE PHYSIOTHERAPY NETWORK LIMITED Firmenbeschreibung
- YORKSHIRE PHYSIOTHERAPY NETWORK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06846871. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 13.03.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 42 Lidget Hill erreicht werden.
Jetzt sichern YORKSHIRE PHYSIOTHERAPY NETWORK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Yorkshire Physiotherapy Network Limited - 42 Lidget Hill, Pudsey, LS28 7DR, England, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu YORKSHIRE PHYSIOTHERAPY NETWORK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-05-25) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-16) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-05-18) - DS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-18) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-09-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-04) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-02) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-02) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-07-02) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-02) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-11-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-18) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-04-03) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-15) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-27) - AA
-
capital-alter-shares-consolidation (2012-06-19) - SH02
-
resolution (2012-06-13) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-12-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-12) - CH01
-
capital-allotment-shares (2010-01-25) - SH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-29) - 88(2)
-
resolution (2009-03-23) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-03-17) - 288b
-
incorporation-company (2009-03-13) - NEWINC