-
JACOB SAMUEL LTD - 7 Powerscroft Road, Sidcup, Kent, DA14 5DT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06931666
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 7 Powerscroft Road
- Sidcup
- Kent
- DA14 5DT 7 Powerscroft Road, Sidcup, Kent, DA14 5DT UK
Management
- Geschäftsführung
- DOYLE, Steven William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.06.2009
- Alter der Firma 2009-06-11 15 Jahre
- SIC/NACE
- 64991
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Steven William Doyle
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- JACOB LEWIS DEVELOPMENTS LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800IUGBLLLD931M05
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-25
- Letzte Einreichung: 2023-06-11
-
JACOB SAMUEL LTD Firmenbeschreibung
- JACOB SAMUEL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06931666. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.06.2009 registriert. JACOB SAMUEL LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JACOB LEWIS DEVELOPMENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64991" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 7 Powerscroft Road erreicht werden.
Jetzt sichern JACOB SAMUEL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jacob Samuel Ltd - 7 Powerscroft Road, Sidcup, Kent, DA14 5DT, Grossbritannien
- 2009-06-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JACOB SAMUEL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-13) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-30) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-12) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-12) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-02-24) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-06) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-02-03) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-15) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-22) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-03-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-24) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-24) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-11-17) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-11-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-08-24) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-08-21) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-08) - CH01
-
resolution (2010-03-05) - RESOLUTIONS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2010-03-05) - SH19
-
legacy (2010-02-11) - CAP-SS
-
legacy (2010-02-11) - SH20
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-06-11) - NEWINC