-
HARRIS ENDEAVOR LIMITED - 25 Palace Street, Berwick-Upon-Tweed, TD15 1HN, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07044124
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25 Palace Street
- Berwick-Upon-Tweed
- TD15 1HN
- England 25 Palace Street, Berwick-Upon-Tweed, TD15 1HN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- EIRLYS LLOYD COMPANY SERVICES LTD
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-15 14 Jahre
- SIC/NACE
- 01110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Avocet Aeroponics Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- AVOCET H2O LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-24
- Letzte Einreichung: 2017-12-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-11-14
- Letzte Einreichung: 2018-10-31
-
HARRIS ENDEAVOR LIMITED Firmenbeschreibung
- HARRIS ENDEAVOR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07044124. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.10.2009 registriert. HARRIS ENDEAVOR LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AVOCET H2O LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01110" registriert. und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/10/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 25 Palace Street erreicht werden.
Jetzt sichern HARRIS ENDEAVOR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Harris Endeavor Limited - 25 Palace Street, Berwick-Upon-Tweed, TD15 1HN, England, Grossbritannien
- 2009-10-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HARRIS ENDEAVOR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-02-06) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-12-29) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-15) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-24) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-01-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-22) - AP01
-
resolution (2019-12-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-07-20) - AP04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-20) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-20) - PSC07
-
resolution (2018-07-23) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-26) - AA01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-24) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-12-19) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-14) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-06) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-06) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-06) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-06) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-11-06) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-05-18) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-24) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-06) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-19) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-10-15) - NEWINC