-
SOUTH WALES KNEE SURGERY LIMITED - - Celtic House, Caxton Place, Pentwyn, Cardiff, Vale Of Glamorgan, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07050518
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- - Celtic House, Caxton Place
- Pentwyn
- Cardiff
- Vale Of Glamorgan
- CF23 8HA - Celtic House, Caxton Place, Pentwyn, Cardiff, Vale Of Glamorgan, CF23 8HA UK
Management
- Geschäftsführung
- ROY, William Stuart, Dr
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-20 14 Jahre
- SIC/NACE
- 96040
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dr William Stuart Roy
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-03
- Letzte Einreichung: 2020-10-20
-
SOUTH WALES KNEE SURGERY LIMITED Firmenbeschreibung
- SOUTH WALES KNEE SURGERY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07050518. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.10.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96040" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über - Celtic House, Caxton Place erreicht werden.
Jetzt sichern SOUTH WALES KNEE SURGERY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: South Wales Knee Surgery Limited - - Celtic House, Caxton Place, Pentwyn, Cardiff, Vale Of Glamorgan, Grossbritannien
- 2009-10-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOUTH WALES KNEE SURGERY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-29) - CS01
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2018-08-02) - DS02
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-27) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-26) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-28) - AAMD
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-11-27) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-27) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-11-27) - AAMD
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2016-12-13) - SOAS(A)
-
gazette-notice-voluntary (2016-11-08) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2016-10-27) - DS01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-12-15) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-13) - AR01
-
resolution (2012-02-23) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-01-26) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2012-01-26) - TM02
-
accounts-amended-with-made-up-date (2012-01-12) - AAMD
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-05-03) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-18) - AA
-
accounts-amended-with-made-up-date (2011-09-05) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2009-10-21) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-10-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2009-10-21) - TM01
-
incorporation-company (2009-10-20) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name (2009-10-21) - TM02