-
P C D BUSINESS SERVICES LTD - 89 Leigh Road, Eatleigh, Hampshire, SO50 9DQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07101244
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 89 Leigh Road
- Eatleigh
- Hampshire
- SO50 9DQ
- England 89 Leigh Road, Eatleigh, Hampshire, SO50 9DQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MCINTOSH, Laura Jayne
- MCINTOSH, Peter Douglas
- MCINTOSH, Peter John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-10 14 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter John Mcintosh
- Mrs. Laura Jayne Mcintosh
- Mr Peter Douglas Mcintosh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-24
- Letzte Einreichung: 2020-12-10
-
P C D BUSINESS SERVICES LTD Firmenbeschreibung
- P C D BUSINESS SERVICES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07101244. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.12.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 89 Leigh Road erreicht werden.
Jetzt sichern P C D BUSINESS SERVICES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: P C D Business Services Ltd - 89 Leigh Road, Eatleigh, Hampshire, SO50 9DQ, Grossbritannien
- 2009-12-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu P C D BUSINESS SERVICES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-04) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-19) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-19) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-23) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-11-11) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2019-09-30) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-19) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-01) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-01) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-20) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-28) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company (2015-11-11) - TM01
-
change-person-director-company (2015-11-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-05) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date (2013-12-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-12-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-30) - CH01
-
change-person-director-company (2012-08-30) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date (2012-12-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-11) - AA
-
capital-allotment-shares (2011-02-18) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-18) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-12-20) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-10) - NEWINC