-
CETRA IT LIMITED - 9th Floor 3 Hardman Street, Manchester, M3 3HF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07190949
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9th Floor 3 Hardman Street
- Manchester
- M3 3HF 9th Floor 3 Hardman Street, Manchester, M3 3HF UK
Management
- Geschäftsführung
- HODARI, Philip Isaac
- RICHARDSON, Keith John
- Prokuristen
- LITTMAN, Wendy
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.03.2010
- Gelöscht am:
- 2021-12-04
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dpco Limited
- Dpco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- HALLCO 1740 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-02-29
- Letzte Einreichung: 2018-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-12
- Letzte Einreichung: 2019-12-01
-
CETRA IT LIMITED Firmenbeschreibung
- CETRA IT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07190949. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.03.2010 registriert. CETRA IT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HALLCO 1740 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 9Th Floor 3 Hardman Street erreicht werden.
Jetzt sichern CETRA IT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cetra It Limited - 9th Floor 3 Hardman Street, Manchester, M3 3HF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CETRA IT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2021-09-04) - LIQ13
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-05-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-03-11) - 600
-
resolution (2020-03-11) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-02-27) - MR04
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-03-11) - LIQ01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-03-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-12) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-06-29) - DISS40
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-27) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-13) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2016-05-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-03-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-02-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-06) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-29) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-21) - AA
-
resolution (2013-04-09) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-11) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-06-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-01-19) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-01-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-09-26) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-12) - AR01
-
second-filing-of-form-with-form-type (2011-08-12) - RP04
-
certificate-change-of-name-company (2011-12-13) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-13) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-12-13) - AP03
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-13) - AP01
-
incorporation-company (2010-03-16) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2010-05-13) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-05-13) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-05-13) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2010-05-13) - TM01