-
GLOBAL FILM & TV SUPPLIES LIMITED - 2 Postley Road, Woburn Road Industrial Estate, Kempston, Bedfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07213507
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Postley Road
- Woburn Road Industrial Estate
- Kempston
- Bedfordshire
- MK42 7BU
- England 2 Postley Road, Woburn Road Industrial Estate, Kempston, Bedfordshire, MK42 7BU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AMBRIDGE, Timothy Lawrence
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-06 14 Jahre
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Timothy Lawrence Ambridge
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GLOBAL FILM SUPPLIES (CRANE & PLANT HIRE) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-07-17
- Letzte Einreichung: 2022-07-03
-
GLOBAL FILM & TV SUPPLIES LIMITED Firmenbeschreibung
- GLOBAL FILM & TV SUPPLIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07213507. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.04.2010 registriert. GLOBAL FILM & TV SUPPLIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GLOBAL FILM SUPPLIES (CRANE & PLANT HIRE) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.04.2012.Die Firma kann schriftlich über 2 Postley Road erreicht werden.
Jetzt sichern GLOBAL FILM & TV SUPPLIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Global Film & Tv Supplies Limited - 2 Postley Road, Woburn Road Industrial Estate, Kempston, Bedfordshire, Grossbritannien
- 2010-04-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GLOBAL FILM & TV SUPPLIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-06-28) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-06-15) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-01-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-29) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-30) - TM01
-
change-of-name-notice (2023-04-26) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2023-04-26) - CERTNM
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-06-13) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-06-13) - PSC07
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-01-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-12) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-10-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-23) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-26) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-16) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-08) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-11) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-01-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-06-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-25) - AD01
-
incorporation-company (2010-04-06) - NEWINC