-
CORNERSTONES TRAINING SOLUTIONS LIMITED - BAILAMS & CO, Ty Antur, Navigation Park, Abercynon, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07213929
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- BAILAMS & CO
- Ty Antur
- Navigation Park
- Abercynon
- Rhondda Cynon Taff
- CF45 4SN BAILAMS & CO, Ty Antur, Navigation Park, Abercynon, Rhondda Cynon Taff, CF45 4SN UK
Management
- Geschäftsführung
- JONES, Huw David Dawson
- Prokuristen
- JONES, Huw David Dawson
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-06 14 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-01-31
- Letzte Einreichung: 2012-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-04-20
- Letzte Einreichung:
-
CORNERSTONES TRAINING SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- CORNERSTONES TRAINING SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07213929. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.04.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Bailams & Co erreicht werden.
Jetzt sichern CORNERSTONES TRAINING SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cornerstones Training Solutions Limited - BAILAMS & CO, Ty Antur, Navigation Park, Abercynon, Grossbritannien
- 2010-04-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CORNERSTONES TRAINING SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-27) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-11-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-11-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-11-10) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-10-28) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2014-09-04) - 4.20
-
resolution (2014-09-04) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2014-09-04) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-28) - AD01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-05-28) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-29) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-08-02) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-05) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-09-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-14) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2012-08-07) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-04-28) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-26) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2012-04-10) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-08-15) - DISS40
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-04) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-10-11) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-10) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2011-08-09) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name (2011-01-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-11-26) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-11-25) - AP01
-
incorporation-company (2010-04-06) - NEWINC