-
P.A. BUSINESS SOLUTIONS LIMITED - The Chapel, Bridge Street, Driffield, YO25 6DA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07216790
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Chapel
- Bridge Street
- Driffield
- YO25 6DA The Chapel, Bridge Street, Driffield, YO25 6DA UK
Management
- Geschäftsführung
- DIXON, Paul Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.04.2010
- Gelöscht am:
- 2024-05-02
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Pabs Holdings (Retford) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-22
- Letzte Einreichung: 2021-04-08
-
P.A. BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- P.A. BUSINESS SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07216790. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 08.04.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.04.2012.Die Firma kann schriftlich über The Chapel erreicht werden.
Jetzt sichern P.A. BUSINESS SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: P.a. Business Solutions Limited - The Chapel, Bridge Street, Driffield, YO25 6DA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu P.A. BUSINESS SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-liquidation (2024-05-02) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2024-02-02) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-11-15) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-11-15) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2023-11-15) - LIQ02
-
resolution (2023-11-15) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2023-04-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-04-25) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-08-25) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-15) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-07-28) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-27) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-12-09) - DISS16(SOAS)
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-26) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-09-26) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-26) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-12) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-29) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-05) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-26) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-02-21) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-18) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-26) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-08-31) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-04-08) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-10-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-10-14) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-09-13) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-15) - AP01