-
MYCOVERPLAN INSURANCE SERVICES LTD - Cobalt Business Exchange, Cobalt Park Way, Wallsend, Newcastle-Upon-Tyne, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07230612
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cobalt Business Exchange
- Cobalt Park Way
- Wallsend
- Newcastle-Upon-Tyne
- NE28 9NZ
- England Cobalt Business Exchange, Cobalt Park Way, Wallsend, Newcastle-Upon-Tyne, NE28 9NZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CLARK, Robert James
- HOWARD, Nicholas Scott
- SMITH, Paul Kenneth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-21 14 Jahre
- SIC/NACE
- 65120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mechanical Breakdown & General Insurance Services Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PINPOINT MARKETING LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-30
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-05
- Letzte Einreichung: 2021-04-21
-
MYCOVERPLAN INSURANCE SERVICES LTD Firmenbeschreibung
- MYCOVERPLAN INSURANCE SERVICES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07230612. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.04.2010 registriert. MYCOVERPLAN INSURANCE SERVICES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PINPOINT MARKETING LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "65120" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Cobalt Business Exchange erreicht werden.
Jetzt sichern MYCOVERPLAN INSURANCE SERVICES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mycoverplan Insurance Services Ltd - Cobalt Business Exchange, Cobalt Park Way, Wallsend, Newcastle-Upon-Tyne, Grossbritannien
- 2010-04-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MYCOVERPLAN INSURANCE SERVICES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-21) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-27) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-16) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-04-04) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-04-03) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-29) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-11) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-06) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-23) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-06) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-17) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-10) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-08) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-12-08) - CERTNM
-
change-of-name-request-comments (2014-12-08) - NM06
-
change-of-name-notice (2014-12-08) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-05-20) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-04) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-05-20) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-15) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-19) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-15) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-05) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2010-07-05) - TM01
-
capital-allotment-shares (2010-06-25) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-25) - AP01
-
incorporation-company (2010-04-21) - NEWINC