-
RTK FARMING LIMITED - Lake House, Market Hill, Royston, Herts, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07278066
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Lake House
- Market Hill
- Royston
- Herts
- SG8 9JN Lake House, Market Hill, Royston, Herts, SG8 9JN UK
Management
- Geschäftsführung
- BANKS, Edward Sidney Oliver
- CROSSLEY, Andrew Philip
- WHITE, David Cecil
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.06.2010
- Alter der Firma 2010-06-09 14 Jahre
- SIC/NACE
- 01610
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Edward Sidney Oliver Banks
- David Cecil White
- Mr Andrew Philip Crossley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-06-23
- Letzte Einreichung: 2024-06-09
-
RTK FARMING LIMITED Firmenbeschreibung
- RTK FARMING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07278066. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01610" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Lake House erreicht werden.
Jetzt sichern RTK FARMING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rtk Farming Limited - Lake House, Market Hill, Royston, Herts, Grossbritannien
- 2010-06-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RTK FARMING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-06-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
capital-allotment-shares (2023-03-20) - SH01
-
resolution (2023-03-20) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-03-20) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-06-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-07-05) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2023-03-17) - PSC09
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-02-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-08-09) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-14) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-14) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-17) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-17) - PSC08
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-13) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-03) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-10-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-06) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-19) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-03-13) - AA01
-
capital-allotment-shares (2012-02-23) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-23) - AP01
-
resolution (2012-02-14) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-06-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-06-09) - NEWINC