-
THE TALBOT AT CHIPPING LTD - St George's House, 215-219 Chester Road, Manchester, M15 4JE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07304468
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- St George's House
- 215-219 Chester Road
- Manchester
- M15 4JE
- United Kingdom St George's House, 215-219 Chester Road, Manchester, M15 4JE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HURT, Clive Edward
- LOWE, Nathan Symon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-05 14 Jahre
- SIC/NACE
- 56302
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Gerald Anthony Lowe
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-19
- Letzte Einreichung: 2021-07-05
-
THE TALBOT AT CHIPPING LTD Firmenbeschreibung
- THE TALBOT AT CHIPPING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07304468. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56302" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.07.2012.Die Firma kann schriftlich über St George's House erreicht werden.
Jetzt sichern THE TALBOT AT CHIPPING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Talbot At Chipping Ltd - St George's House, 215-219 Chester Road, Manchester, M15 4JE, Grossbritannien
- 2010-07-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE TALBOT AT CHIPPING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-02-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-10-06) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-10-07) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-25) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-07-07) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-16) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-08) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-07) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-26) - AA
-
termination-director-company (2018-09-12) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-12) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-18) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-12-11) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-18) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-11-09) - TM01
-
capital-allotment-shares (2011-11-09) - SH01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-07-05) - NEWINC