-
CHRISTOPHER BROOK CARS LIMITED - Suite One Peel Mill Commercial Street, Morley, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07456327
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite One Peel Mill Commercial Street
- Morley
- Leeds
- West Yorkshire
- LS27 8AG Suite One Peel Mill Commercial Street, Morley, Leeds, West Yorkshire, LS27 8AG UK
Management
- Geschäftsführung
- LINDLEY, George William Jake
- LINDLEY, Thomas Richard Brook
- Prokuristen
- SEDDON, Jason David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-01 13 Jahre
- SIC/NACE
- 45112
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr George Lindley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-04-12
- Letzte Einreichung: 2024-03-29
-
CHRISTOPHER BROOK CARS LIMITED Firmenbeschreibung
- CHRISTOPHER BROOK CARS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07456327. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45112" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite One Peel Mill Commercial Street erreicht werden.
Jetzt sichern CHRISTOPHER BROOK CARS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Christopher Brook Cars Limited - Suite One Peel Mill Commercial Street, Morley, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2010-12-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHRISTOPHER BROOK CARS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-04-12) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-04-12) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-04-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-29) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-01) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2023-03-30) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-12-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-26) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-07-14) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-07-14) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-12-18) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-16) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-12-21) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-21) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-02-24) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-01) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-03) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-12-03) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2010-12-03) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-12-03) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-12-03) - AD01