-
EMBARGO FILMS LIMITED - 5th Floor 111 Charterhouse Street, London, EC1M 6AW, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07462659
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5th Floor 111 Charterhouse Street
- London
- EC1M 6AW
- England 5th Floor 111 Charterhouse Street, London, EC1M 6AW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SIMON, Christopher Charles
- SOUTHCOMBE, Barnaby James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-07 13 Jahre
- SIC/NACE
- 59111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Christopher Charles Simon
- Mr Barnaby James Southcombe
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-14
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
-
EMBARGO FILMS LIMITED Firmenbeschreibung
- EMBARGO FILMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07462659. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 5Th Floor 111 Charterhouse Street erreicht werden.
Jetzt sichern EMBARGO FILMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Embargo Films Limited - 5th Floor 111 Charterhouse Street, London, EC1M 6AW, England, Grossbritannien
- 2010-12-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EMBARGO FILMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-11-28) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-12-08) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-09-27) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-30) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-08) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-18) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-05-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-10) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-09-26) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-02-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-02-21) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-08-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-04-17) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-14) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-12-12) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2012-12-11) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-02-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-07) - NEWINC