-
BLUE DIAMOND SURGERY SUPPLIES LIMITED - Craiglas House Maerdy Industrial Estate, Rhymney, Tredegar, Gwent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07505953
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Craiglas House Maerdy Industrial Estate
- Rhymney
- Tredegar
- Gwent
- NP22 5PY
- United Kingdom Craiglas House Maerdy Industrial Estate, Rhymney, Tredegar, Gwent, NP22 5PY, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- COSTIGAN, Conor Francis
- HAMER, Hugh Lloyd
- KEENAN, Harry
- MCEVOY, Redmond
- MORAN, Caroline
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-26 13 Jahre
- SIC/NACE
- 46760
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Williams Medical Supplies Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-02-08
- Letzte Einreichung: 2024-01-25
-
BLUE DIAMOND SURGERY SUPPLIES LIMITED Firmenbeschreibung
- BLUE DIAMOND SURGERY SUPPLIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07505953. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46760" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Craiglas House Maerdy Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern BLUE DIAMOND SURGERY SUPPLIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blue Diamond Surgery Supplies Limited - Craiglas House Maerdy Industrial Estate, Rhymney, Tredegar, Gwent, Grossbritannien
- 2011-01-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLUE DIAMOND SURGERY SUPPLIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-08-12) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-07-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-19) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-19) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-19) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-19) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-20) - AP01
-
resolution (2018-03-27) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-03-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-16) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-26) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-01) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-10-24) - MR04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-02-22) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-22) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-02-22) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-01-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-30) - AA
-
legacy (2012-01-17) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-03-14) - AA01
-
incorporation-company (2011-01-26) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-10-11) - AD01