-
OPES FINANCIAL PARTNERS LIMITED - Sterling House, 27 Hatchlands Road, Redhill, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07556710
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Sterling House
- 27 Hatchlands Road
- Redhill
- Surrey
- RH1 6RW Sterling House, 27 Hatchlands Road, Redhill, Surrey, RH1 6RW UK
Management
- Geschäftsführung
- RASHID, Masood
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.03.2011
- Alter der Firma 2011-03-08 13 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Masood Rashid
- Mr Masood Rashid
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-29
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-22
- Letzte Einreichung: 2023-03-08
-
OPES FINANCIAL PARTNERS LIMITED Firmenbeschreibung
- OPES FINANCIAL PARTNERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07556710. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.03.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Sterling House erreicht werden.
Jetzt sichern OPES FINANCIAL PARTNERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Opes Financial Partners Limited - Sterling House, 27 Hatchlands Road, Redhill, Surrey, Grossbritannien
- 2011-03-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OPES FINANCIAL PARTNERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-08-09) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-10) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-06-28) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-10) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-02-24) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-02-23) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-02-21) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-02-21) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-12-14) - PSC01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-18) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-20) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-20) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-08) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-13) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-05) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-10) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-01) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-13) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-12-13) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-09) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-06-13) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-01-31) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-03-08) - NEWINC