-
HEALTHCARE 21 (HOLDINGS) LIMITED - Jubilee House Third Avenue, Globe Park, Marlow, SL7 1EY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07592452
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Jubilee House Third Avenue
- Globe Park
- Marlow
- SL7 1EY
- England Jubilee House Third Avenue, Globe Park, Marlow, SL7 1EY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- O'BRIEN, Dennis Simon
- SKELTON, Toby Matthew
- WYATT, Clifford
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.04.2011
- Alter der Firma 2011-04-05 13 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Clifford Wyatt
- Lucid Group Communications Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-04-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-19
- Letzte Einreichung: 2021-04-05
-
HEALTHCARE 21 (HOLDINGS) LIMITED Firmenbeschreibung
- HEALTHCARE 21 (HOLDINGS) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07592452. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.04.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.04.2014.Die Firma kann schriftlich über Jubilee House Third Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern HEALTHCARE 21 (HOLDINGS) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Healthcare 21 (Holdings) Limited - Jubilee House Third Avenue, Globe Park, Marlow, SL7 1EY, Grossbritannien
- 2011-04-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HEALTHCARE 21 (HOLDINGS) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-10-11) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-30) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-03) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-06-04) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-27) - CS01
-
resolution (2020-05-05) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-05-05) - MA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-30) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-04-28) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-09-12) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-09-12) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-09-12) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-12) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-05) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-07-07) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
gazette-notice-compulsary (2013-08-06) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-28) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-08-07) - DISS40
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-21) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-05-24) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-16) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-07) - TM01
-
incorporation-company (2011-04-05) - NEWINC