-
SAMBA STYLE LIMITED - CVR GLOBAL LLP, 1st Floor 16-17 Boundary Road, Hove, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07593804
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- CVR GLOBAL LLP
- 1st Floor 16-17 Boundary Road
- Hove CVR GLOBAL LLP, 1st Floor 16-17 Boundary Road, Hove UK
Management
- Geschäftsführung
- PARACHA, Jehanzeb Karim
- Prokuristen
- PARACHA, Jehanzeb Karim
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.04.2011
- Gelöscht am:
- 2020-04-30
- SIC/NACE
- 14390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Alies Debruyn
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- TANGO GROUP INTERNATIONAL SALES LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 21380028SOAFB5AZ9Q35
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-03-31
- Letzte Einreichung: 2016-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-06
-
SAMBA STYLE LIMITED Firmenbeschreibung
- SAMBA STYLE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07593804. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.04.2011 registriert. SAMBA STYLE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TANGO GROUP INTERNATIONAL SALES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "14390" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Cvr Global Llp erreicht werden.
Jetzt sichern SAMBA STYLE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Samba Style Limited - CVR GLOBAL LLP, 1st Floor 16-17 Boundary Road, Hove, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SAMBA STYLE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-04-30) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-01-30) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-12-27) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-03-03) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-12-27) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-28) - AA
-
resolution (2017-05-12) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-06-17) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-07) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-10-15) - AP03
-
resolution (2017-12-22) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-12-22) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-12-22) - LIQ02
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-15) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-29) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-14) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-11-09) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-14) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-05-22) - TM01
-
resolution (2013-03-21) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2013-03-21) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-01-04) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-04-11) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-11) - AR01
-
legacy (2012-10-03) - MG01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-10-05) - CH03
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-05) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-08-10) - MG01
-
legacy (2011-07-06) - MG01
-
legacy (2011-06-29) - MG01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-06-09) - AP03
-
resolution (2011-04-14) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2011-04-14) - CONNOT
-
incorporation-company (2011-04-06) - NEWINC