-
JAZZ FINANCING UK LIMITED - Wing B, Building 5700, Spires House John Smith Drive, Oxford Business Park South, Oxford, OX4 2RW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07597461
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Wing B, Building 5700, Spires House John Smith Drive
- Oxford Business Park South
- Oxford
- OX4 2RW Wing B, Building 5700, Spires House John Smith Drive, Oxford Business Park South, Oxford, OX4 2RW UK
Management
- Geschäftsführung
- PEARCE, Samantha
- Prokuristen
- DOODY, Aislinn Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.04.2011
- Alter der Firma 2011-04-08 13 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Jazz Pharmaceuticals Lux S.À R.L.
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- EUSA PHARMA (EUROPE) UK LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-04-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-22
- Letzte Einreichung: 2021-04-08
-
JAZZ FINANCING UK LIMITED Firmenbeschreibung
- JAZZ FINANCING UK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07597461. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.04.2011 registriert. JAZZ FINANCING UK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen EUSA PHARMA (EUROPE) UK LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.04.2014.Die Firma kann schriftlich über Wing B, Building 5700, Spires House John Smith Drive erreicht werden.
Jetzt sichern JAZZ FINANCING UK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jazz Financing Uk Limited - Wing B, Building 5700, Spires House John Smith Drive, Oxford Business Park South, Oxford, OX4 2RW, Grossbritannien
- 2011-04-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JAZZ FINANCING UK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-10-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-15) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-15) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-07-09) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-28) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-11) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-04-10) - CH03
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-22) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2015-08-12) - CERTNM
-
gazette-notice-voluntary (2015-02-24) - GAZ1(A)
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-14) - AA
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2015-05-21) - DS02
-
resolution (2015-02-19) - RESOLUTIONS
-
dissolution-application-strike-off-company (2015-02-16) - DS01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-24) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-12) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-05-10) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2013-02-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-10-04) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-05-13) - AP03
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-10-16) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-10-09) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-10-05) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-10-02) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2012-10-02) - TM02
-
legacy (2012-07-03) - MG02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-04-08) - NEWINC
-
legacy (2011-05-10) - MG01