-
CITADEL MARITIME LIMITED - 12 Whiteladies Road Clifton, Bristol, BS8 1PD, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07653883
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 12 Whiteladies Road Clifton
- Bristol
- BS8 1PD
- United Kingdom 12 Whiteladies Road Clifton, Bristol, BS8 1PD, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-01 13 Jahre
- SIC/NACE
- 80100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Matthew Anthony Mark Kingston
- Mr Nicholas John Leishman Clarke
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-26
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-01
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-15
- Letzte Einreichung: 2023-06-01
-
CITADEL MARITIME LIMITED Firmenbeschreibung
- CITADEL MARITIME LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07653883. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.06.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "80100" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 01.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 12 Whiteladies Road Clifton erreicht werden.
Jetzt sichern CITADEL MARITIME LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Citadel Maritime Limited - 12 Whiteladies Road Clifton, Bristol, BS8 1PD, United Kingdom, Grossbritannien
- 2011-06-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CITADEL MARITIME LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-06-26) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-06-26) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2023-11-28) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-12-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-11-29) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-30) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-12-01) - DISS40
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-06-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-04-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-11) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-29) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-29) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-06) - AA
-
resolution (2014-12-01) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-12-01) - SH02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-30) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-16) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-02) - AR01
-
resolution (2013-04-10) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2013-04-10) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-04-10) - SH03
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-09) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-08-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-07) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-06-27) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-08) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-06-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-07-18) - TM01
-
incorporation-company (2011-06-01) - NEWINC