-
DISPLAYPAK ECO LTD - Unit 5 Little Reed Street, Hull, HU2 8JL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07669108
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 5 Little Reed Street
- Hull
- HU2 8JL Unit 5 Little Reed Street, Hull, HU2 8JL UK
Management
- Geschäftsführung
- DEARMAN, Andrew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-14 13 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Andrew Dearman
- Mr Andrew Dearman
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- HARNESS THE SUN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-07-31
- Letzte Einreichung: 2021-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-06-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-07
- Letzte Einreichung: 2022-08-24
-
DISPLAYPAK ECO LTD Firmenbeschreibung
- DISPLAYPAK ECO LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07669108. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.06.2011 registriert. DISPLAYPAK ECO LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HARNESS THE SUN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.06.2014.Die Firma kann schriftlich über Unit 5 Little Reed Street erreicht werden.
Jetzt sichern DISPLAYPAK ECO LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Displaypak Eco Ltd - Unit 5 Little Reed Street, Hull, HU2 8JL, Grossbritannien
- 2011-06-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DISPLAYPAK ECO LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-05-20) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2023-05-20) - LIQ02
-
resolution (2023-05-20) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-05-20) - 600
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-08-24) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-24) - CS01
-
certificate-change-of-name-company (2021-11-25) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-24) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-24) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-06-20) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-20) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-20) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-20) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-12) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-04) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-23) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-12) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-16) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-16) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-16) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-24) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-04-17) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-09) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-11-28) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-30) - AR01
-
legacy (2012-11-27) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-09-12) - AA
-
legacy (2012-11-20) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-06-14) - NEWINC