-
MASTERING LIMITED - Albany House, Claremont Lane, Esher, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07811453
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Albany House
- Claremont Lane
- Esher
- Surrey
- KT10 9FQ Albany House, Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9FQ UK
Management
- Geschäftsführung
- BURGESS, Stephen Derek
- SERKEBAEVA, Kamila
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.10.2011
- Gelöscht am:
- 2023-12-05
- SIC/NACE
- 59200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Air Studios (Lyndhurst) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-07-26
- Letzte Einreichung: 2021-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-31
- Letzte Einreichung: 2022-10-17
-
MASTERING LIMITED Firmenbeschreibung
- MASTERING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07811453. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 17.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Albany House erreicht werden.
Jetzt sichern MASTERING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mastering Limited - Albany House, Claremont Lane, Esher, Surrey, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MASTERING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-04-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-07-26) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-04-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2021-03-12) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-03) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-03-03) - TM02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-10-20) - PSC07
-
resolution (2021-06-17) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-20) - CS01
-
legacy (2021-06-17) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-06-17) - SH19
-
legacy (2021-06-17) - CAP-SS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-10-20) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-21) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-21) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-10) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-03-06) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-21) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-07) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-02-09) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-03) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-23) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-03-20) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-23) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-02-23) - CH03
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-08-08) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-05-20) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-12) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-11-12) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-11-07) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-10-17) - TM01
-
incorporation-company (2011-10-17) - NEWINC