-
BHT LIQ LTD. - Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07811601
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Jupiter House Warley Hill Business Park
- The Drive
- Brentwood
- Essex
- CM13 3BE Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, CM13 3BE UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-17 12 Jahre
- SIC/NACE
- 42110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter Whitmore
- Mr Peter Whitmore
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- THAMES HYDROBLASTING LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-28
- Letzte Einreichung: 2019-10-17
-
BHT LIQ LTD. Firmenbeschreibung
- BHT LIQ LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07811601. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.10.2011 registriert. BHT LIQ LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THAMES HYDROBLASTING LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "42110" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Jupiter House Warley Hill Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern BHT LIQ LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bht Liq Ltd. - Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
- 2011-10-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BHT LIQ LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
certificate-change-of-name-company (2020-10-29) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2020-10-06) - CONNOT
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-08-17) - LIQ02
-
resolution (2020-08-17) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-08-17) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-21) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-01-22) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-01-23) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-01-13) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-12) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-01-09) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-20) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-06) - PSC04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-06) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-27) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-06) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-08-04) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-08-04) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2013-06-14) - SH10
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-20) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-06-14) - SH08
-
resolution (2013-06-14) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-11) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-04-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-04-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-25) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-10-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-12-20) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2011-12-19) - TM01
-
incorporation-company (2011-10-17) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2011-10-21) - AP01