-
PEGMOS LIMITED - 79 Caroline Street, Birmingham, B3 1UP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07853517
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 79 Caroline Street
- Birmingham
- B3 1UP 79 Caroline Street, Birmingham, B3 1UP UK
Management
- Geschäftsführung
- MOSELEY, Christopher David
- PEGLEY, Alexis James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.11.2011
- Alter der Firma 2011-11-18 12 Jahre
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alexis James Pegley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- CALCULIS FINANCIAL PLANNERS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-15
- Letzte Einreichung: 2020-07-01
-
PEGMOS LIMITED Firmenbeschreibung
- PEGMOS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07853517. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.11.2011 registriert. PEGMOS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CALCULIS FINANCIAL PLANNERS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.11.2012.Die Firma kann schriftlich über 79 Caroline Street erreicht werden.
Jetzt sichern PEGMOS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pegmos Limited - 79 Caroline Street, Birmingham, B3 1UP, Grossbritannien
- 2011-11-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PEGMOS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-05-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-01-13) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-01-14) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-company-meeting (2022-01-25) - LIQ11
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-05-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
resolution (2021-03-24) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-03-24) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-03-24) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-01) - CS01
-
resolution (2020-04-16) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-06) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-15) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-21) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-11-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-19) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-11-21) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-05) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-07) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-16) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-11-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-10) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-06-22) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-11-18) - NEWINC