-
KONG CV1 LIMITED - Bank Gallery, High Street, Kenilworth, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07879194
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bank Gallery
- High Street
- Kenilworth
- Warwickshire
- CV8 1LY
- England Bank Gallery, High Street, Kenilworth, Warwickshire, CV8 1LY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MOLONEY, Garry
- MOLONEY, Vanessa
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-12 12 Jahre
- SIC/NACE
- 47721
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mrs Vanessa Moloney
- Mr Garry Moloney
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-12-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-26
- Letzte Einreichung: 2023-12-12
-
KONG CV1 LIMITED Firmenbeschreibung
- KONG CV1 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07879194. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.12.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47721" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.12.2013.Die Firma kann schriftlich über Bank Gallery erreicht werden.
Jetzt sichern KONG CV1 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kong Cv1 Limited - Bank Gallery, High Street, Kenilworth, Warwickshire, Grossbritannien
- 2011-12-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KONG CV1 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-08-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-06) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-05-05) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-05-05) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-04) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-24) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-26) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-26) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-11-28) - SH03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-16) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-02) - MR01
-
capital-cancellation-shares (2017-11-28) - SH06
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-26) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-31) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-24) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-07) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-08) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-07-08) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-07-08) - SH01
-
resolution (2014-07-16) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-14) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-07-16) - SH08
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-12) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-09-11) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-24) - MG01
-
capital-allotment-shares (2012-02-06) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-12-19) - TM01
-
incorporation-company (2011-12-12) - NEWINC