-
CHRISTOPHER ROWE LIMITED - Old Printers Yard, 156 South Street, Dorking, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07888275
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Old Printers Yard
- 156 South Street
- Dorking
- Surrey
- RH4 2HF
- England Old Printers Yard, 156 South Street, Dorking, Surrey, RH4 2HF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ALLORI, David Gabriel
- ANSCOMBE, Paul Anthony
- BRATT, Diana Marie
- ROE, Alan Michael
- SWANN, Andrew David
- TURNER, Paul Andrew
- Prokuristen
- SWANN, Andrew David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-20 12 Jahre
- SIC/NACE
- 66220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Kathleen Rowe
- Seventeen Group Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-29
- Letzte Einreichung: 2020-12-15
-
CHRISTOPHER ROWE LIMITED Firmenbeschreibung
- CHRISTOPHER ROWE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07888275. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.12.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66220" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Old Printers Yard erreicht werden.
Jetzt sichern CHRISTOPHER ROWE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Christopher Rowe Limited - Old Printers Yard, 156 South Street, Dorking, Surrey, Grossbritannien
- 2011-12-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHRISTOPHER ROWE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-05-21) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-05-13) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-05-13) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-13) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-05-13) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-05-13) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-05-13) - AP03
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-12) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-13) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-18) - CS01
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2018-11-22) - SH02
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-09-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2017-12-20) - SH02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-15) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-22) - CS01
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2016-12-08) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-15) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-11) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-01-16) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-07-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-28) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-20) - NEWINC