-
MD ROMSEY LTD - Nightingale Pharmacy, Great Well Drive, Romsey, SO51 7QP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08111262
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Nightingale Pharmacy
- Great Well Drive
- Romsey
- SO51 7QP
- England Nightingale Pharmacy, Great Well Drive, Romsey, SO51 7QP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- THAKRAR, Kaushik Mohanlal
- THAKRAR, Mitakumari
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.06.2012
- Alter der Firma 2012-06-19 12 Jahre
- SIC/NACE
- 47730
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Aasha (Retail) Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- RUSHPORT (ROMSEY) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2023-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-06-24
- Letzte Einreichung: 2024-06-10
-
MD ROMSEY LTD Firmenbeschreibung
- MD ROMSEY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08111262. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.06.2012 registriert. MD ROMSEY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RUSHPORT (ROMSEY) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47730" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Nightingale Pharmacy erreicht werden.
Jetzt sichern MD ROMSEY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Md Romsey Ltd - Nightingale Pharmacy, Great Well Drive, Romsey, SO51 7QP, Grossbritannien
- 2012-06-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MD ROMSEY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2024-06-07) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-06-10) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-06-10) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-06-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-06-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2024-06-10) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-06-10) - MR04
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-11-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-24) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-02) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-07-01) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-24) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-02) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-11) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-11) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-02-12) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-11) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-11) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-26) - AD01
-
resolution (2020-03-26) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-07) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-19) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-10-16) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-11-07) - SH01
-
resolution (2012-11-07) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-15) - AP01
-
incorporation-company (2012-06-19) - NEWINC