-
AMIANTE STR LTD - Eversley Haulage Park Brickhouse Hill, Eversley, Hook, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08114992
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Eversley Haulage Park Brickhouse Hill
- Eversley
- Hook
- Hampshire
- RG27 0PZ
- England Eversley Haulage Park Brickhouse Hill, Eversley, Hook, Hampshire, RG27 0PZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COLLARD, Robert John
- Prokuristen
- WILCOCK, David Ian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.06.2012
- Alter der Firma 2012-06-21 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Collard Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-09-30
- Letzte Einreichung: 2023-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-07-05
- Letzte Einreichung: 2024-06-21
-
AMIANTE STR LTD Firmenbeschreibung
- AMIANTE STR LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08114992. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.06.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Eversley Haulage Park Brickhouse Hill erreicht werden.
Jetzt sichern AMIANTE STR LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Amiante Str Ltd - Eversley Haulage Park Brickhouse Hill, Eversley, Hook, Hampshire, Grossbritannien
- 2012-06-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AMIANTE STR LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2024-01-23) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2024-01-23) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-06-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2024-09-02) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-09-14) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-10-31) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2022-10-31) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-10-31) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-09-15) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-06-14) - PSC07
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2022-06-13) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-06-13) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-06-13) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-06-13) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-15) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-14) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-07) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-29) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-05) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-10-21) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-06-21) - NEWINC