-
TICKVANTAGE LTD - BTMR LIMITED, Century Buildings, 14 St. Mary's Parsonage, Manchester, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08143409
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- BTMR LIMITED
- Century Buildings
- 14 St. Mary's Parsonage
- Manchester
- M3 2DF BTMR LIMITED, Century Buildings, 14 St. Mary's Parsonage, Manchester, M3 2DF UK
Management
- Geschäftsführung
- TEJI, Tarlok Nath
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-13 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Tarlok Teji
- Mr Tarlok Nath Teji
- Mr Tarlok Teji
- 20 Twenty Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-07-31
- Letzte Einreichung: 2018-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-07-27
- Letzte Einreichung: 2019-07-13
-
TICKVANTAGE LTD Firmenbeschreibung
- TICKVANTAGE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08143409. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Btmr Limited erreicht werden.
Jetzt sichern TICKVANTAGE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tickvantage Ltd - BTMR LIMITED, Century Buildings, 14 St. Mary's Parsonage, Manchester, Grossbritannien
- 2012-07-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TICKVANTAGE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-allotment-shares (2019-08-02) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-10-03) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-01) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-18) - PSC05
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-28) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-07-24) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-25) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-11-12) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-11) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2016-10-11) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-07) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-15) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-31) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-01-20) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-06-02) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-11) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-19) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-11) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-11) - AP01
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2013-08-19) - AP02
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-19) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-07) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-07-02) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-11) - AD01
-
incorporation-company (2012-07-13) - NEWINC