-
PATENT BOX CONSULTANTS LIMITED - 2nd Floor Churchill House, 26-30 Upper Marlborough Road, St. Albans, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08158246
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor Churchill House
- 26-30 Upper Marlborough Road
- St. Albans
- Hertfordshire
- AL1 3UU
- England 2nd Floor Churchill House, 26-30 Upper Marlborough Road, St. Albans, Hertfordshire, AL1 3UU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HAMM, Luke Giuilio
- PHILLIPS, Steven John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-26 12 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Government Grant & Tax Consultants Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-06-30
- Letzte Einreichung: 2023-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-09
- Letzte Einreichung: 2023-07-26
-
PATENT BOX CONSULTANTS LIMITED Firmenbeschreibung
- PATENT BOX CONSULTANTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08158246. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.07.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor Churchill House erreicht werden.
Jetzt sichern PATENT BOX CONSULTANTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Patent Box Consultants Limited - 2nd Floor Churchill House, 26-30 Upper Marlborough Road, St. Albans, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2012-07-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PATENT BOX CONSULTANTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2024-05-30) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2024-06-14) - DS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-03-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-05-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-06-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-05) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-12) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-06) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-27) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-31) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-31) - PSC02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-28) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-09) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-09) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-04-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-10-21) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-06) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-26) - NEWINC