-
SPRAY’S BAKERIES LIMITED - 80 Lambourne Road, Chigwell, IG7 6EN, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08210977
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 80 Lambourne Road
- Chigwell
- IG7 6EN
- England 80 Lambourne Road, Chigwell, IG7 6EN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SPRAY, Michael David
- SPRAY, Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.09.2012
- Alter der Firma 2012-09-12 11 Jahre
- SIC/NACE
- 10710
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter Spray
- Mr Michael David Spray
- Mr Peter Spray
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-26
- Letzte Einreichung: 2023-09-12
-
SPRAY’S BAKERIES LIMITED Firmenbeschreibung
- SPRAY’S BAKERIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08210977. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.09.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10710" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 80 Lambourne Road erreicht werden.
Jetzt sichern SPRAY’S BAKERIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Spray’S Bakeries Limited - 80 Lambourne Road, Chigwell, IG7 6EN, England, Grossbritannien
- 2012-09-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SPRAY’S BAKERIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-06-03) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-03) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-01) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-21) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-21) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-07) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-12-06) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-06) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-25) - PSC04
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-05-20) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-16) - AR01
-
legacy (2013-03-22) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-05) - AP01
-
incorporation-company (2012-09-12) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2012-10-05) - TM01