-
SABA INFRA CAMBRIDGESHIRE LIMITED - Second Floor, Building 4 Croxley Park, Hatters Lane, Watford, WD18 8YF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08246194
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Second Floor, Building 4 Croxley Park
- Hatters Lane
- Watford
- WD18 8YF
- United Kingdom Second Floor, Building 4 Croxley Park, Hatters Lane, Watford, WD18 8YF, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HERRING, Phillip David
- ORIOL CARRERAS, Josep
- PICKARD, Gary Charles
- Prokuristen
- PICKARD, Gary Charles
- MICHELMORES SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.10.2012
- Alter der Firma 2012-10-09 11 Jahre
- SIC/NACE
- 52290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Saba Infra Uk Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- INDIGO INFRA CAMBRIDGESHIRE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-14
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
-
SABA INFRA CAMBRIDGESHIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- SABA INFRA CAMBRIDGESHIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08246194. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.10.2012 registriert. SABA INFRA CAMBRIDGESHIRE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen INDIGO INFRA CAMBRIDGESHIRE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52290" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 2 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Second Floor, Building 4 Croxley Park erreicht werden.
Jetzt sichern SABA INFRA CAMBRIDGESHIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Saba Infra Cambridgeshire Limited - Second Floor, Building 4 Croxley Park, Hatters Lane, Watford, WD18 8YF, Grossbritannien
- 2012-10-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SABA INFRA CAMBRIDGESHIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-08-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-11-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-03) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-17) - PSC05
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-07-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-11) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-02-11) - PSC05
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-05) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-26) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-06-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-03) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-11) - TM01
-
resolution (2018-12-19) - RESOLUTIONS
-
resolution (2018-12-28) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-03) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-02-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-08-17) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-12) - CS01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-10-11) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-21) - AA
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-10-11) - AD03
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-11-05) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-21) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-10-16) - AP03
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-10-14) - AP04
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-02) - AA
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2015-03-06) - MR05
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-03-06) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-07-11) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2014-07-11) - MA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-15) - MR01
-
auditors-resignation-company (2014-10-23) - AUD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-14) - AR01
-
miscellaneous (2014-10-31) - MISC
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-11-27) - AA01
-
incorporation-company (2012-10-09) - NEWINC