-
NEWBAY MEDIA UK HOLDCO LIMITED - Quay House, The Ambury, Bath, BA1 1UA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08304765
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Quay House
- The Ambury
- Bath
- BA1 1UA
- England Quay House, The Ambury, Bath, BA1 1UA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BYNG-THORNE, Zillah Ellen
- MAW, Timothy Ian
- ROBBINS, Michael Andrew
- ADDISON, Rachel Bernadette
- Prokuristen
- MAW, Timothy Ian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.11.2012
- Gelöscht am:
- 2020-09-29
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Future Holdings 2002 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-06-30
- Letzte Einreichung: 2018-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-05-15
- Letzte Einreichung: 2019-05-01
-
NEWBAY MEDIA UK HOLDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- NEWBAY MEDIA UK HOLDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08304765. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.11.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Quay House erreicht werden.
Jetzt sichern NEWBAY MEDIA UK HOLDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Newbay Media Uk Holdco Limited - Quay House, The Ambury, Bath, BA1 1UA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEWBAY MEDIA UK HOLDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-12) - AP01
-
gazette-notice-voluntary (2020-03-31) - GAZ1(A)
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-11) - AP01
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-03-24) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-04-02) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-04) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-20) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-02) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-01) - CS01
-
legacy (2019-05-29) - GUARANTEE2
-
legacy (2019-05-29) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-05-29) - AGREEMENT2
-
resolution (2019-10-24) - RESOLUTIONS
-
legacy (2019-10-24) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-10-24) - SH19
-
legacy (2019-10-24) - SH20
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-11-28) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-11-28) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-11) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-02) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-02) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-05-11) - PSC09
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-05-11) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-19) - TM01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2018-09-04) - RP04AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-03) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-02-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-09) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-06) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-18) - PSC08
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-18) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-02-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-07) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-04-19) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-03-28) - SH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-03-20) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-20) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-03-24) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-05-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-28) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-02) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-17) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-12-13) - MG01
-
incorporation-company (2012-11-22) - NEWINC